Elizabeth SPRAUER

Elizabeth SPRAUER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Elizabeth SPRAUER [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 10. September 1866 Alexandria, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
Bestattung 1960 Saints Peter and Paul Church Cemetery, Gubser, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Tod 16. Februar 1960 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33] [34] [35] [36] [37]
Wohnen 1900 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1910 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1920 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1930 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Heirat 5. März 1889 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42] [43]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
5. März 1889
Campbell, Kentucky, USA
Eugene MEYER

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T625_564; Page: 9B; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Page: 2A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 18 Feb 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103709386/?article=38936c95-b96e-4c5c-8fbf-6eb6f706826c&focus=0.12967905,0.8220427,0.23387119,0.8659135&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T625_564; Page: 9B; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Page: 2A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 18 Feb 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103709386/?article=38936c95-b96e-4c5c-8fbf-6eb6f706826c&focus=0.12967905,0.8220427,0.23387119,0.8659135&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T625_564; Page: 9B; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Page: 2A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 18 Feb 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103709386/?article=38936c95-b96e-4c5c-8fbf-6eb6f706826c&focus=0.12967905,0.8220427,0.23387119,0.8659135&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T625_564; Page: 9B; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Page: 2A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person