Rose DRESSMANN

Rose DRESSMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Rose DRESSMANN [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 26. November 1878 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
Bestattung 1940 Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Tod 3. Juli 1940 Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39]
Wohnen 1880 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Heirat 27. August 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [47]
Heirat 20. April 1924 Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [48]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
27. August 1900
Covington, Kenton, Kentucky, USA
Albert Harry MASCHMEYER
Heirat Ehepartner Kinder
20. April 1924
Hamilton, Ohio, USA
George H MEIMANN

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 425; Page: 372C; Enumeration District: 120
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 6; Enumeration District: 0111; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 9A; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Will Books, 1858-1924; Indexes, 1858-1939; Author: Kenton County (Kentucky). Clerk of the County Court
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Newspapers.com Marriage Index, 1800s-1999, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 27/ Apr/ 1975; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/101524348/?article=c909cecb-6b83-4410-b5c0-103a768079ba&focus=0.64421934,0.055592295,0.7598973,0.2787665&xid=3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 6; Enumeration District: 0111; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 9A; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Will Books, 1858-1924; Indexes, 1858-1939; Author: Kenton County (Kentucky). Clerk of the County Court
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Newspapers.com Marriage Index, 1800s-1999, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 27/ Apr/ 1975; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/101524348/?article=c909cecb-6b83-4410-b5c0-103a768079ba&focus=0.64421934,0.055592295,0.7598973,0.2787665&xid=3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 6; Enumeration District: 0111; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 9A; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 425; Page: 372C; Enumeration District: 120
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 6; Enumeration District: 0111; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 9A; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person