Walter Tolbert FITZWATER

Walter Tolbert FITZWATER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Walter Tolbert FITZWATER [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 22. September 1891 Bracken, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Bestattung 1933 Linden Grove Cemetery, Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Tod 24. Dezember 1933 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34] [35] [36] [37]
Wohnen 1900 Magisterial District 1, Nicholas, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1920 Huntington Ward 3, Cabell, West Virginia, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0019; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Magisterial District 1, Nicholas, Kentucky; Roll: 546; Page: 15; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240546
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 7A; Enumeration District: 0081; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 3 Jun 1967; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100678431/?article=f0addee7-df9b-470a-85eb-2c500f91e7ef&focus=0.7263751,0.5780067,0.8329772,0.6318886&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0019; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Magisterial District 1, Nicholas, Kentucky; Roll: 546; Page: 15; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240546
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 7A; Enumeration District: 0081; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 3 Jun 1967; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100678431/?article=f0addee7-df9b-470a-85eb-2c500f91e7ef&focus=0.7263751,0.5780067,0.8329772,0.6318886&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0019; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Magisterial District 1, Nicholas, Kentucky; Roll: 546; Page: 15; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240546
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 7A; Enumeration District: 0081; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Magisterial District 1, Nicholas, Kentucky; Roll: 546; Page: 15; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240546
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 7A; Enumeration District: 0081; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0019; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person