Albert Joseph KONEN

Albert Joseph KONEN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Albert Joseph KONEN [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Juli 1900 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
Bestattung 1943 Saint Stephen Cemetery, Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Tod 24. Juni 1943 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30] [31] [32] [33]
Wohnen 1920 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1930 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1940 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1942 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38] [39]
Wohnen 1943 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Agnes Gertrude LINTKER

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 370
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 12B; Enumeration District: 19-25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 6, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 8A; Enumeration District: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 29A; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 27 Jun 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103225883/?article=720818f7-5340-4821-ac29-af660b7b1ff7&focus=0.2630444,0.3765915,0.3781059,0.42725366&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Veterans Administration Master Index, 1917-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 370
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 12B; Enumeration District: 19-25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 6, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 8A; Enumeration District: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 29A; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 27 Jun 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103225883/?article=720818f7-5340-4821-ac29-af660b7b1ff7&focus=0.2630444,0.3765915,0.3781059,0.42725366&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S., Veterans Administration Master Index, 1917-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 370
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 12B; Enumeration District: 19-25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 6, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 8A; Enumeration District: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 29A; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., Veterans Administration Master Index, 1917-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 27 Jun 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103225883/?article=720818f7-5340-4821-ac29-af660b7b1ff7&focus=0.2630444,0.3765915,0.3781059,0.42725366&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., Veterans Administration Master Index, 1917-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 6, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 8A; Enumeration District: 36
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 29A; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 12B; Enumeration District: 19-25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 12B; Enumeration District: 19-25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 370
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 U.S., Veterans Administration Master Index, 1917-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person