Frank Fred BENKE

Frank Fred BENKE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Frank Fred BENKE [20] [21]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 15. April 1894 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24]
Bestattung 1964 Saint Stephen Cemetery, Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25]
Tod 24. Januar 1964 Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1910 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Campbell County, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1930 Bellevue, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1935 Bellevue, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1940 Bellevue, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1942 Bellevue, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1950 Bellevue, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen vor 1951 Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 016
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 7; Enumeration District: 0023; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T624_467; Page: 8A; Enumeration District: 0029; FHL microfilm: 1374480
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Web: Cincinnati, Ohio, U.S., Spring Grove Cemetery Index, 1845-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 18 Jan 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100821459/?article=155d419d-4be9-4e75-a534-93c54d5980d7&focus=0.65541303,0.33019233,0.77021456,0.38786432&xid=33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 7; Enumeration District: 0023; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 7; Enumeration District: 0023; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T624_467; Page: 8A; Enumeration District: 0029; FHL microfilm: 1374480
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 016
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1950 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person