William ROTHENBERGER

William ROTHENBERGER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name William ROTHENBERGER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 17. Oktober 1847 Alzey, Hessen, Darmstadt, Hesse, Germany nach diesem Ort suchen [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Bestattung Middle Village, Queens County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [23]
Tod 10. März 1888 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [24] [25]
Einbürgerung 5. März 1878 New York, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1875 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1880 New York City, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [28] [29]
Wohnen 1888 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [31]
Departure etwa 1866 Mainz, Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, Deutschland nach diesem Ort suchen [32]
Arrival 11. Juni 1866 New York, New York nach diesem Ort suchen [33]
Regina Happel Rothenberger 7. Juli 1881 Middle Village, Queens County, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Arrival New York nach diesem Ort suchen [35]
Departure Hamburg, Germany nach diesem Ort suchen [36]
Heirat 28. Juli 1872 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [37] [38]
Heirat 13. Mai 1882 New York nach diesem Ort suchen [39]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. Juli 1872
Manhattan, New York, USA
Regina HAPPEL
Heirat Ehepartner Kinder
13. Mai 1882
New York
Anna MEISSNER

Quellenangaben

1 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Mainz, Germany, Emigration Register, 1856-1877
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 871; Page: 400B; Enumeration District: 089
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1866; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 267; Line: 37; List Number: 633
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York City, Compiled Marriage Index, 1600s-1800s
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Presbyterian Church Records, 1701-1970, Presbyterian Historical Society; Philadelphia, Pennsylvania; Book Title: 1872 - 1885
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York, Wills and Probate Records, 1659-1999, Record of Wills, 1665-1916; Index to Wills, 1662-1923 (New York County); Author: New York. Surrogate's Court (New York County); Probate Place: New York, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S., Presbyterian Church Records, 1701-1970, Presbyterian Historical Society; Philadelphia, Pennsylvania; Book Title: 1872 - 1893
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Mainz, Germany, Emigration Register, 1856-1877
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 871; Page: 400B; Enumeration District: 089
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1866; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 267; Line: 37; List Number: 633
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Presbyterian Church Records, 1701-1970, Presbyterian Historical Society; Philadelphia, Pennsylvania; Book Title: 1872 - 1893
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Wills and Probate Records, 1659-1999, Record of Wills, 1665-1916; Index to Wills, 1662-1923 (New York County); Author: New York. Surrogate's Court (New York County); Probate Place: New York, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940, National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 871; Page: 400B; Enumeration District: 089
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Microfilm Serial: M1674; Microfilm Roll: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Mainz, Germany, Emigration Register, 1856-1877
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1866; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 267; Line: 37; List Number: 633
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Findagrave, Regina Happel Rothenberger 7 Jul 1881
35 New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1866; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 267; Line: 37; List Number: 633
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 New York City, Compiled Marriage Index, 1600s-1800s
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person