Elizabeth Beth ANDERSON

Elizabeth Beth ANDERSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Elizabeth Beth ANDERSON [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 2. August 1900 Coatbridge, Lanarkshire, Scotland nach diesem Ort suchen [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Tod 1975 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "12 Sept 1975") Grand Rapids, Kent, Michigan, United States of America nach diesem Ort suchen [15] [16]
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1920 Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1901 Old Monkland, Lanarkshire, Scotland nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen Scotland nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [22]
Arrival 1909 [23]
Arrival 23. Februar 1910 New York, New York nach diesem Ort suchen [24]
Departure Glasgow, Scotland nach diesem Ort suchen [25]
Arrival 1910 [26]
Heirat 31. Mai 1923 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Mai 1923
Grand Rapids, Kent, Michigan
Abram Baynton HORNER SR.
Heirat Ehepartner Kinder

Lawrence HUTCHINSON

Quellenangaben

1 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Michigan, Death Index, 1971-1996
Autor: Michigan Department of Vital and Health Records
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1901 Scotland Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 Michigan, Death Index, 1971-1996
Autor: Michigan Department of Vital and Health Records
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1901 Scotland Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Michigan, Death Index, 1971-1996
Autor: Michigan Department of Vital and Health Records
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1901 Scotland Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Michigan, Death Index, 1971-1996
Autor: Michigan Department of Vital and Health Records
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person