Elizabeth Beth ANDERSON
♀ Elizabeth Beth ANDERSON
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Elizabeth Beth ANDERSON | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 2. August 1900 | Coatbridge, Lanarkshire, Scotland nach diesem Ort suchen | [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Tod | 1975 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "12 Sept 1975") | Grand Rapids, Kent, Michigan, United States of America nach diesem Ort suchen | [15] [16] |
Wohnen | 1. April 1940 | Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen | [17] |
Wohnen | 1920 | Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [18] |
Wohnen | 1901 | Old Monkland, Lanarkshire, Scotland nach diesem Ort suchen | [19] |
Wohnen | Scotland nach diesem Ort suchen | [20] | |
Wohnen | Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [21] | |
Wohnen | 1930 | Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [22] |
Arrival | 1909 | [23] | |
Arrival | 23. Februar 1910 | New York, New York nach diesem Ort suchen | [24] |
Departure | Glasgow, Scotland nach diesem Ort suchen | [25] | |
Arrival | 1910 | [26] | |
Heirat | 31. Mai 1923 | Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen |
Eltern
John H. ANDERSON | Jane CAMPBELL |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
31. Mai 1923 Grand Rapids, Kent, Michigan |
Abram Baynton HORNER SR. |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
Lawrence HUTCHINSON |
|
Quellenangaben
1 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
2 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | Michigan, Death Index, 1971-1996 Autor: Michigan Department of Vital and Health Records Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
5 | 1901 Scotland Census Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
8 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
10 | Michigan, Death Index, 1971-1996 Autor: Michigan Department of Vital and Health Records Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
11 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | 1901 Scotland Census Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
13 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 370-16-9104; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | Michigan, Death Index, 1971-1996 Autor: Michigan Department of Vital and Health Records Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
17 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
18 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | 1901 Scotland Census Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
20 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
21 | Michigan, Death Index, 1971-1996 Autor: Michigan Department of Vital and Health Records Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
22 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
23 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 2A; Enumeration District: 50; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
24 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
25 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1910; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1414; Line: 7; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
26 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |