Abram Baynton HORNER SR.

Abram Baynton HORNER SR.

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Abram Baynton HORNER SR. [1] [2] [3] [4] [5]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 12. August 1885 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [6] [7] [8] [9] [10]
Tod 1948 Grand Rapids, Michigan nach diesem Ort suchen
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [14]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1918 Saginaw, Michigan nach diesem Ort suchen [16]
Heirat 31. Mai 1923 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen
Heirat 18. Juni 1914 Grand Rapids, Michigan nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Mai 1923
Grand Rapids, Kent, Michigan
Elizabeth Beth ANDERSON
Heirat Ehepartner Kinder
18. Juni 1914
Grand Rapids, Michigan
Leona L ENSLEY

Quellenangaben

1 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Genesee County, Michigan; Roll: 1675434; Draft Board: 1.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Genesee County, Michigan; Roll: 1675434; Draft Board: 1.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1901; Page: 6B; Enumeration District: 86-136.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Genesee County, Michigan; Roll: 1675434; Draft Board: 1.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person