Edward A. TAYLERT

Edward A. TAYLERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Edward A. TAYLERT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 8. November 1908 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Bestattung 28. Februar 1968 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26]
Tod 20. Februar 1968 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1954 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Heirat 20. September 1928 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38] [39] [40]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
20. September 1928
Rochester, Monroe, New York, USA
Evelyn J GEREW

Notizen zu dieser Person

Social Security Death Index Recordinfo about Edward Taylert Name: Edward Taylert SSN: 079-14-7379 Last Residence: 14621 Rochester, Monroe, New York, USA of Ameri ca Born: 8 Nov 1908 Died: Feb 1968 State (Year) SSN issued: New York (Before 1951 )

Quellenangaben

1 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
2 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 079-14-7379; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 5A; Enumeration District: 65-351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
13 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
14 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
15 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
16 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 079-14-7379; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 5A; Enumeration District: 65-351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
24 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
25 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
27 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
28 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 079-14-7379; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 5A; Enumeration District: 65-351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 5A; Enumeration District: 65-351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
37 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
39 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
40 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person