Louis Joseph TAYLERT

Louis Joseph TAYLERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Louis Joseph TAYLERT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 13. August 1881 Germany nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung 29. April 1946 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Tod 25. April 1946 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26]
Wohnen 1942 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1936 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Arrival 1885 [37] [38] [39]
Buried 29. April 1946 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Heirat 31. Dezember 1904 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Dezember 1904
Rochester, Monroe, New York, USA
Mary Ann SCHICKER

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
13 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
14 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
15 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 Diocese of Rochester records on microfilm at Nazareth College Library, Roll, 6, Item 19, Most Holy Redeemer Church, Marriages, p322 (& Baptisms, Item 12, 1905 #61, 1910 #4)
23 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
26 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
27 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 0185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
39 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 4B; Enumeration District: 187; Image: 131
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
40 Diocese of Rochester records on microfilm at Nazareth College Library, Roll, 6, Item 19, Most Holy Redeemer Church, Marriages, p322

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person