Bernice C. TAYLERT

Bernice C. TAYLERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Bernice C. TAYLERT [1] [2] [3] [4] [5]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [6] [7]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [8]
Tod 21. Oktober 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [9] [10]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12]

Quellenangaben

1 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
4 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
5 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
6 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
10 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
11 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person