Catherine Adele HORNER

Catherine Adele HORNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Catherine Adele HORNER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 12. September 1897 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Tod 24. März 1988 Ada, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1920 Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 3. April 1922 Grand Rapids, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [24]
Arrival 4. August 1922 Quebec nach diesem Ort suchen [25]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Arthur Clay HAMILTON

Quellenangaben

1 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 374-46-6697; Issue State: Michigan; Issue Date: 1962.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 8B; Enumeration District: 99; Image: 356.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 18A; Enumeration District: 86-177.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 374-46-6697; Issue State: Michigan; Issue Date: 1962.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 8B; Enumeration District: 99; Image: 356.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 18A; Enumeration District: 86-177.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 374-46-6697; Issue State: Michigan; Issue Date: 1962.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 18A; Enumeration District: 86-177.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 8B; Enumeration District: 99; Image: 356.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person