Sarah Elizabeth KNOWLSON

Sarah Elizabeth KNOWLSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Sarah Elizabeth KNOWLSON [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. Februar 1860 Albany, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Tod 22. Mai 1948 Grand Rapids,Michigan,USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1875 Royalton, Niagara, New York nach diesem Ort suchen
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1920 Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1880 Gasport/Royalton, Niagara, New York, United States nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1870 Royalton, Niagara, New York nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 11. Februar 1860 Albany Ward 8, Albany, New York nach diesem Ort suchen [31]
Arrival 1939 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1922 and 1938 and 1939") [32] [33] [34]
Heirat 12. August 1884 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
12. August 1884
Grand Rapids, Kent, Michigan
Joseph HORNER SR

Quellenangaben

1 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: , , ; Roll: M593
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Albany Ward 8, Albany, New York; Roll: M653_720; Page: 60; Image: 62.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Gasport, Niagara, New York; Roll: T9_901; Family History Film: 1254901; Page: 315.3000; Enumeration District: 190; Image: 0211.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_6281; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 1A; Enumeration District: 86-176A.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Web: Kent County, Michigan, Marriage Index, 1842-1929
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: , , ; Roll: M593
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Albany Ward 8, Albany, New York; Roll: M653_720; Page: 60; Image: 62.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Gasport, Niagara, New York; Roll: T9_901; Family History Film: 1254901; Page: 315.3000; Enumeration District: 190; Image: 0211.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_6281; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 1A; Enumeration District: 86-176A.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: T627_1902; Page: 1A; Enumeration District: 86-176A.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Gasport, Niagara, New York; Roll: T9_901; Family History Film: 1254901; Page: 315.3000; Enumeration District: 190; Image: 0211.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: , , ; Roll: M593
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Albany Ward 8, Albany, New York; Roll: M653_720; Page: 60; Image: 62.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_6281; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person