Joseph HORNER SR

Joseph HORNER SR

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Joseph HORNER SR [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 19. November 1861 Pateley Bridge, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
Tod 27. Mai 1957 Grand Rapids, Kent, Michigan, USA nach diesem Ort suchen [34] [35]
Einwanderung 16. August 1880 from England to Grand Rapids, Michigan, United States nach diesem Ort suchen
Einbürgerung 1887 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "20 Sept 1887") Grand Rapids, Michigan nach diesem Ort suchen
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1. April 1940 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1890 Grand Rapids, MI nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1878 Pocklington, Yorkshire, , England nach diesem Ort suchen
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1881 Tyersal, Bradford, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1920 Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1881 Pocklington, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [42] [43]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1871 Yeadon, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 4. Februar 1920 Grand Rapids, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [47]
Departure 1911 Yorkshire, England nach diesem Ort suchen
Departure Liverpool, England and Queenstown, Ireland nach diesem Ort suchen [48]
Arrival 16. August 1880 New York nach diesem Ort suchen [49]
Arrival 30. Januar 1938 Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen [50] [51] [52]
Departure 1927 Kingston, Jamaica nach diesem Ort suchen [53]
Heirat 12. August 1884 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen
Heirat 1949 Grand Rapids, Michigan nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
12. August 1884
Grand Rapids, Kent, Michigan
Sarah Elizabeth KNOWLSON
Heirat Ehepartner Kinder
1949
Grand Rapids, Michigan
Erna WEIDENFELLER

Quellenangaben

1 Appleton Post Crescent (Appleton, Wisconsin)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1878; Arrival: , ; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_414; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1927; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_4014; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1911; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1714; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 379-12-1287; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1881 England Census, Class: RG11; Piece: 4484; Folio: 23; Page: 39; GSU roll: 1342074.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 35; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 England & Wales, Civil Registration Birth Index, 1837-1915
Autor: FreeBMD
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Grand Rapids, Michigan City Directories, 1889-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 Web: Kent County, Michigan, Marriage Index, 1842-1929
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1878; Arrival: , ; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_414; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1927; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_4014; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1911; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1714; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 379-12-1287; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1881 England Census, Class: RG11; Piece: 4484; Folio: 23; Page: 39; GSU roll: 1342074.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 35; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 England & Wales, Civil Registration Birth Index, 1837-1915
Autor: FreeBMD
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1911; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_1714; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 379-12-1287; Issue State: Michigan; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 Grand Rapids, Michigan City Directories, 1889-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 1881 England Census, Class: RG11; Piece: 4484; Folio: 23; Page: 39; GSU roll: 1342074.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Grand Rapids Ward 2, Kent, Michigan; Roll: T625_777; Page: 1B; Enumeration District: 51; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42
43
44 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1004; Page: 3B; Enumeration District: 100; Image: 385.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 23B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
46 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 U.S. Passport Applications, 1795-1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 35; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 35; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
50 New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
51 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1878; Arrival: , ; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_414; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1927; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_4014; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1927; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_4014; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person